BOOKSINSPIRED Actief
0866.724.001 - 1390 Grez-Doiceau

BOOKSINSPIRED State gazette publications

02/01/2024 Objet - statuts (traduction, coordination, autres modifications, …) - modification forme juridique
27/07/2018 Intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 21/06/2018
27/07/2018 Date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office : 21/06/2018
23/03/2018 Ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 13/03/2018
23/03/2018 Date de la prise d'effet de la radiation d'office : 13/03/2018
03/10/2014 Siege social - demissions, nominations - statuts (traduction, coordination, autres modifications, …)
04/06/2007 Ontslagen - benoemingen
24/03/2006 Maatschappelijke zetel
19/12/2005 Maatschappelijke zetel
08/11/2005 Kapitaal - aandelen - algemene vergadering - statuten (vertaling, coÖrdinatie, overige wijzigingen, …)
26/08/2004 Rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor, enz...)

BOOKSINSPIRED Annual account download as Excel file

03/07/2018 ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 20.03.2015, DPT 21.06.2018 18213-0531-018
03/07/2018 ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 18.03.2016, DPT 21.06.2018 18213-0522-016
18/05/2018 ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 07.05.2018, DPT 08.05.2018 18125-0571-015
24/06/2014 ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.03.2014, DPT 20.06.2014 14194-0202-016
30/04/2014 ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 29.03.2013, DPT 25.04.2014 14100-0480-014
05/03/2013 ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.03.2012, DPT 27.02.2013 13051-0157-013
28/09/2011 ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 27.07.2011, DPT 22.09.2011 11552-0399-011
27/08/2010 ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.08.2010, NGL 24.08.2010 10436-0021-015
05/05/2009 ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.03.2009, NGL 30.04.2009 09127-0361-015
14/10/2008 ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 19.09.2008, NGL 08.10.2008 08777-0023-015
25/05/2007 ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 16.05.2007, NGL 21.05.2007 07148-0230-017
04/04/2006 ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 27.03.2006, NGL 31.03.2006 06096-1948-016